Place Index 5

THE FAMILIES OF JOE AND JERRY GRANT
Place Index 5

Main Page - Master Index - Surname Index - Master Place Index - Home Page
Previous Page - Next Page



South Carolina
Newberry County
13 miles north east Newberry
   Haynie, Frances   b. 1767, d. 1843
   Ruff, Cecilia Sims   b. c 1835
   Ruff, Charles Neville   b. c 1843
   Ruff, Christian   b. b 1748, d. c 1797
   Ruff, Fredrick Christian   b. 6 Apr 1809, d. 22 Aug 1844
   Ruff, Jeanette Henry   b. 1839, d. 1867
   Ruff, John   b. s 1769, d. c 1819
   Ruff, John Calhoun   b. 1851, d. 1852
   Ruff, Maximillian   b. 25 Dec 1812, d. 18 Aug 1867
   Ruff, Moorman   b. c 1856
   Ruff, Reuben Fredrick   b. 1837, d. 1861
   Ruff, William Walton   b. 1841, d. 1864
   Yost, Barbara   b. s 1751, d. c 1796
Little Mt
   Hipp, Christina   b. c 1813, d. a 1880
   Hipp, John IV   b. c 1815, d. 28 Aug 1879
   Hipp, Susannah Margaret   b. c 1809
near Pomaria
   Counts, John (Capt.)   b. c 1765, d. 24 Jun 1847
   Counts, William M.   b. 22 Feb 1801, d. 22 Dec 1848
   Eichelberger, Elizabeth   b. 8 Aug 1768, d. 14 Dec 1835
   Eichelberger, Mary Ursala   b. 1 May 1760, d. 20 Oct 1838
   Eichelberger, Susannah Margaret   b. c 1764, d. 25 Apr 1815
   Gray, George Jr.   b. 16 Aug 1756, d. 27 Jan 1826
   Gray, John Peter   b. 16 Aug 1768, d. 18 Oct 1844
   Hipp, William Andrew   b. 19 Feb 1825, d. 8 Jan 1901
   Ruff, George Oliver   b. 31 Dec 1817, d. 7 Dec 1855
   Ruff, John Henry   b. 12 Aug 1773, d. 25 Dec 1835
   Ruff, Rebecca   b. 18 Apr 1807, d. 13 Apr 1879
   Ruff, Salome (Sarah)   b. c 1780, d. 9 Sep 1861
   Summer, Margaret Elizabeth   b. c 1772, d. 1 Jul 1848
Newberry
   Ruff, Henry Jr.   b. 14 Dec 1786, d. 7 Jun 1856
   Summer, Marie Eve   b. c 1788
Peak
   Hipp, Elizabeth   b. 4 Sep 1801, d. 21 May 1891
York County
   McDowell, Jane   b. 2 Sep 1766, d. 20 Apr 1853
South Carolina or Georgia
   Travis, Eustacey   b. 13 Jun 1814, d. 23 May 1894
Tennessee
   Bennett, Evaline   b. c 1834
   Graves, Daniel Lewis   b. 1858
   Graves, John Andrew   b. 27 Apr 1863, d. 5 Jan 1933
   Graves, Nancy Ann (Cissy)   b. 1862
   Graves, William LaFayette   b. 1855, d. 30 Dec 1923
   Moor, Nancy   b. c 1780, d. s 1860
   Rogers, Joseph Larkin   b. 19 Aug 1794, d. 8 Jul 1878
   Wilson, Hugh C.   b. 21 Jan 1826, d. 20 Aug 1895
   Wilson, Mary   b. s 1789
   Wilson, Telitha Elizabeth   b. 17 Nov 1844, d. 25 May 1893
   Wilson, William S.   b. c 1824, d. a 11 Jun 1990
Bedford
   Russell, Elizabeth   b. 23 Feb 1815, d. 5 Aug 1850
   Wilson, Matthew   b. 8 Mar 1808, d. 6 Jul 1887
Bedford County
Eagleville
   Wilson, David Russell   b. 9 May 1825, d. 22 May 1910
   Wilson, John L.   b. 1827
Chapel Hill
   Wilson, Elizabeth   b. 12 Oct 1795, d. 3 Oct 1844
Coffee County
Manchester
   Allison, Luretha Jane   b. 11 Nov 1823, d. 22 Nov 1894
   Wilson, Simon Elliot   b. 15 Feb 1820, d. 22 Nov 1894
Giles County
   Goodnight, Elizabeth   b. c 1790
   Ruff, Catherine Elizabeth "Lizzie"   b. 1828
   Ruff, Daniel Perry   b. c 1830
   Ruff, David Crockett   b. c 1821, d. 19 Oct 1869
   Ruff, Frances L.   b. c 1831
   Ruff, Godsend   b. c 1755, d. c 1820
   Ruff, Henry Lewis   b. c 1822, d. 11 Feb 1904
   Ruff, John   b. c 1785, d. c 1840
   Ruff, Johnathan Wesley   b. c 1823, d. 1862
   Ruff, Martha Jane   b. c 1830
   Ruff, Mary Caroline   b. b Jun 1834, d. 10 Jan 1929
   Ruff, Nancy "Nance" Adeline   b. b Jun 1834
   Ruff, Presley B.   b. c 1818, d. a 1845
Hamilton County
Chattanooga
   Griffin, Kelsey Lamar Jr.   b. 14 Nov 1944, d. 30 Jul 1974
Marshall County
   Williams, James   b. 26 Dec 1785, d. 1850
   Williams, Martha   b. c 1828
   Williams, Nancy   b. c 1825, d. c 1850
   Williams, Sarah   b. c 1820
   Wilson, Aaron A.   b. 1751, d. 1833
   Wilson, Issac Shook   b. 13 Mar 1827, d. 25 Sep 1851
   Wilson, James   b. 25 Sep 1757, d. 11 Apr 1843
   Wilson, Joseph   b. 1749, d. 1833
   Wilson, Josiah F.   b. Oct 1767, d. 1851
   Wilson, Moses   b. Jul 1769, d. 18 Jul 1850
   Wilson, Samuel   b. 1762, d. 1813
   Wilson, Thomas   b. 1763, d. 1845
   Wilson, William S.   b. c 1824, d. a 11 Jun 1990
near Gallatin
   Wilson, Major David   b. c 1742, d. c 1803
Summer
Hendersonville
   Savell, Nancy Ruth   b. 24 Mar 1954, d. 6 May 2003
Sumner County
   Moor, Nancy   b. c 1780, d. s 1860
   Wilson, David Jr.   b. c 1785
   Wilson, Elizabeth   b. c 1772
   Wilson, James   b. c 1780
   Wilson, Major David   b. c 1742, d. c 1803
   Wilson, Mary   b. c 1802
   Wilson, Samuel   b. s 1725, d. 9 Apr 1814
   Wilson, Samuel   b. s 1800, d. b 1857
   Wilson, William   b. c 1777
   Wilson, Zaccheus (Zacherus)   b. c 1782
   Wilson, Zachaus (Zaccheus)   b. c 1772, d. b 1814
Hendersonville
   Savell, Nancy Ruth   b. 24 Mar 1954, d. 6 May 2003
Warren County
   Whitlock, John   b. 25 Jan 1797, d. 14 Apr 1881
Warren, County
   Whitlock, John   b. 25 Jan 1797, d. 14 Apr 1881
Williamson
   Ramsey, Robert   b. c 1789
   Wilson, Elizabeth   b. 12 Oct 1795, d. 3 Oct 1844
Williamson County
   Baucum, Nancy   b. s 1814
   Baucum, William   b. s 1785
   White, Nancy   b. s 1812
   Wilson, Aaron   b. s 1815
   Wilson, Benjamin Thomas   b. c 1835
   Wilson, James B.   b. c 1833
   Wilson, Janet T.   b. 25 Sep 1844, d. 9 Aug 1900
   Wilson, Josiah F. Jr.   b. 1811, d. 14 Aug 1857
   Wilson, Margaret   b. s 1790
   Wilson, Mary   b. s 1789
   Wilson, Mary A. (Margaret ?)   b. c 1836
   Wilson, Mary C.   b. c 1819
   Wilson, Matthew   b. 8 Mar 1808, d. 6 Jul 1887
   Wilson, Robert   b. s 1791
   Wilson, Samuel   b. s 1793
   Wilson, Thomas P.   b. 1805
   Wilson, Zaccheus   b. Nov 1765, d. 21 Oct 1842
   Wilson, Zaccheus Jr.   b. 1803, d. 6 Dec 1843
   Wilson, Zaccheus M.   b. 9 Jul 1841, d. 25 Feb 1865
Wilson
   Graves, James   b. c 1869
Alexandria
   Graves, Lewis   b. 11 Sep 1826, d. 4 Jun 1894
Wilson County
   (Whitlock), Nancy   b. s 1847
   Bennett, Evaline   b. c 1834
   Edwards, Nancy Jane   b. s 1829
   Graves, Andrew Carroll   b. c 1831, d. 6 Sep 1904
   Graves, Lewis   b. 11 Sep 1826, d. 4 Jun 1894
   Graves, Lewis Esq.   b. c 1789, d. 1857
   Graves, Minerva   b. c 1828
   Graves, Nancy   b. c 1825
   Graves, William   b. s 1824
   Starnes, Rebecca   b. c 1789, d. Mar 1858
   Starnes, Wesley   b. 12 May 1819, d. Jul 1860
   Whitlock, Abner Brown   b. c 1843, d. 1925
   Whitlock, Mary Malinda   b. 29 Nov 1846, d. 20 Feb 1925
Lebanon
   West, Nancy   b. s 1800
   Whitlock, John   b. 25 Jan 1797, d. 14 Apr 1881
Statesville
   Graves, Doctor Franklin   b. c 1876, d. 1942
   Graves, Jennetta (Nettie)   b. 1872, d. 1946
   Graves, Lewis Bethel   b. 25 Oct 1867, d. 3 Feb 1938
   Graves, Robert E.   b. c 1870
   Graves, Thomas A.   b. 13 Aug 1873, d. 31 May 1940
Texas
   (Graves), Maggie   b. 13 Apr 1871, d. 30 Jan 1918
   (Graves), Wilma A. ?   b. 1906, d. 1998
   (Rogers), Leliah F.   b. 1837
   Andrews, John W.   b. c 1883
   Basham, Emmett E.   b. 20 Jul 1895, d. 5 Feb 1964
   Boston, Jefferson Davis   b. 19 Sep 1861, d. 10 Aug 1958
   Eichelberger,, Susanna C.   b. 26 May 1838, d. 1935
   Elrod, Delia Lee   b. 10 Jan 1890, d. 2 Jun 1949
   Gibson, Audie   b. 28 Aug 1891, d. 16 Dec 1932
   Graves, Daniel Lewis   b. 1858
   Graves, Ettie   b. 16 Sep 1899, d. 10 Mar 1984
   Graves, John Andrew   b. 27 Apr 1863, d. 5 Jan 1933
   Graves, Nancy Ann (Cissy)   b. 1862
   Lefevre, Amanda   b. c 1872
   Lefevre, Anna C.   b. c 1862
   Lefevre, Augustus   b. c 1810, d. c 1888
   Lefevre, Augustus   b. c 1876
   Lefevre, Claud Elmer   b. 23 Apr 1890, d. 4 Mar 1961
   Lefevre, Elmer Lee   b. 7 May 1911, d. 25 May 1991
   Lefevre, G. B.   b. 8 Jan 1914, d. 1990
   Lefevre, John Thomas   b. 3 Oct 1926, d. 30 Jan 1993
   Lefevre, Katie Lee   b. 25 Nov 1896, d. a 1976
   Lefevre, Lillie E.   b. c 1880
   Lefevre, Martha J   b. Jul 1884
   Lefevre, Mary E.   b. c 1873
   Lefevre, Minnie O   b. Aug 1886
   Lefevre, Olivia B.   b. c 1867
   Lefevre, Ophelia N.   b. Oct 1881
   Lefevre, Roland D   b. Dec 1882
   Lefevre, Thomas Jacob   b. 9 Nov 1908, d. 14 Feb 1963
   Lefevre, William Jefferson   b. 19 Sep 1871
   Lefevre, wineford   b. c 1871
   Maples, Mollie Corina   b. 30 Aug 1873, d. 5 Jul 1965
   Oglesby, G F   b. c 1858
   Oglesby, Martha   b. c May 1860
   Ragsdale, Debbie Ann   b. 2 Feb 1875, d. 2 Mar 1893
   Rogers, Franklin R.   b. 1875
   Rogers, James G.   b. 1877
   Rogers, John Franklin   b. 7 Feb 1866, d. 14 May 1951
   Rogers, John T.   b. 1873
   Rogers, M. Ellen   b. 1859
   Rogers, Martha A.   b. 1872
   Rogers, Olin Duglass   b. 21 Jun 1910, d. 7 Feb 1986
   Rogers, Tee   b. 29 Aug 1907, d. 12 Aug 1978
   Rogers, Thomas   b. 1835
   Rowley, May   b. Aug 1876
   Shannon, Jerome D   b. c 1901, d. 10 Mar 1963
   Simpson, Lottie   b. c 1880
   Tarpley, Emma L.   b. 27 Jan 1865, d. 21 Feb 1899
   Terry, Claude R. (See_also_Jerome D._Shannon)   b. c 1901
   Vaughn, Martha   b. c 1850
   Ward, J. Clarence
   Whitenburg, David Moore   b. 22 Sep 1894
   Whitenburg, Jacob Benjamin   b. 14 Dec 1888
   Whitenburg, John Calvin   b. 5 Oct 1892
   Whitenburg, Katheryn Elizabeth   b. 2 Dec 1897
   Whitenburg, Tennie Frances   b. 24 Dec 1899, d. 14 Dec 1902
   Whitenburg, William Heard   b. 14 Jul 1890, d. 13 Jun 1892
   Wilson, Mary M.   b. s 1836
   Wilson, Sarah E.   b. c 1839
   Wilson, William S.   b. c 1824, d. a 11 Jun 1990
Anderson
   Blackshear, Samatha   b. c 1835, d. b 1865
   Rogers, John   b. 9 May 1828, d. 3 May 1907
Plenitude
   Rogers, John   b. 9 May 1828, d. 3 May 1907
   Rogers, S R   b. c 1853
Angelina County
Lufkin
   Lefevre, Clayton   b. 10 Nov 1913, d. c 1980
Bailey County
Muleshoe
   Armstrong, Albert Gather   b. 19 Jan 1893, d. 16 Nov 1956
Bell County
   Armstrong, Harry Tracy   b. 16 Jun 1895, d. 16 Jun 1967
Bexar County
San Antonia
   Armstrong, Donald Earnest   b. 9 Sep 1909, d. 4 Nov 1976
   Armstrong, Jimmie H.   b. 30 Mar 1912, d. 1 May 1961
   Erkson, Della   b. c 1910
   Travis, William Barrett   b. 1 Aug 1809, d. 6 Mar 1836
Bexer County
San Antonio
   Travis, William Barrett   b. 1 Aug 1809, d. 6 Mar 1836
Bosque County
   Cunningham, Leota V.   b. 1 May 1900, d. 15 Jan 1935
   Graves, Bertie Paralee   b. 10 Feb 1897, d. 6 Aug 1993
   Lefevre, Francis Regis (Bud)   b. c 1857, d. 28 Dec 1932
   Lefevre, Rhoda Ellen Ophelia   b. 14 Mar 1874, d. 31 Aug 1976
   Ragsdale, Debbie Ann   b. 2 Feb 1875, d. 2 Mar 1893
   Stinebaugh, Laura Etta
Walnut Springs
   Berry, Phoebe J.   b. s 1860, d. 1890
   Cunningham, Leota V.   b. 1 May 1900, d. 15 Jan 1935
   McCloud, Mary   b. c 1834, d. 11 Jan 1890
Bowie County
New Boston
   Ruff, George W.   b. 12 Sep 1836, d. 17 Oct 1915
Brazos County
   ?) Lefevre, Octavia (Jane   b. c 1862
   Berry, Phoebe J.   b. s 1860, d. 1890
   Hartman, Simon A.   b. c 1849
   Hulbert, William   b. c 1850
   Lefevre, Alford   b. c 1876
   Lefevre, Amanda   b. c 1872
   Lefevre, Ambers Flournoy   b. c 1868, d. 12 Feb 1934
   Lefevre, Anna C.   b. c 1862
   Lefevre, Augustus   b. c 1876
   Lefevre, Belvedere   b. c 1865
   Lefevre, Cornelius Augustus   b. 16 Sep 1834
   Lefevre, Emily   b. c 1847
   Lefevre, Frances Virginia   b. 9 Mar 1854
   Lefevre, Francis Regis (Bud)   b. c 1857, d. 28 Dec 1932
   Lefevre, James Monroe   b. c 1860
   Lefevre, Julia Orbele   b. 1 Jul 1852
   Lefevre, Lillie E.   b. c 1880
   Lefevre, Olivia B.   b. c 1867
   Lefevre, Victor   b. c 1872
   Massey, M. M.   b. s 1862
   McCloud, Mary   b. c 1834, d. 11 Jan 1890
   Warren, Martha J.   b. 2 May 1843, d. 19 May 1907
Boonesville
   Lefevre, Augustus   b. c 1810, d. c 1888
Brown County
Brownwood
   Graves, Dossie A.   b. 11 Mar 1905, d. 11 Aug 1941
   Graves, Robert E. (R.E.)   b. 13 Jan 1921, d. 1993
Chapel Hill
   Travis, Charles Edward   b. 1 Aug 1829, d. 8 Dec 1860
Cherokee
   Rogers, John   b. 9 May 1828, d. 3 May 1907
Clay
Newport
   Gill, Charles Ewing   b. 17 Feb 1821, d. 9 Dec 1905
Coryell
   Lefevre, Frances E.   b. c 1836
   Lefevre, Mary Ophelia   b. 23 Oct 1843
   Oglesby, Mary E   b. 20 Jun 1847, d. Jul 1880
Gatesville
   Lefevre, Mary Ophelia   b. 23 Oct 1843
   Oglesby, Charles F.   b. c 1820
   Oglesby, Willis   b. c 1845, d. b 1880
Coryell County
   (Whitlock), Minerva   b. 13 Jun 1821, d. 10 Jun 1910
   Beachum, Mary Jane   b. s 1869
   Blackshear, Tabitha Melvina   b. 11 May 1838, d. 12 Nov 1909
   Gibson, Ira J.   b. 1869, d. 1931
   Graves, Andrew Thomas   b. c 1876
   Graves, Cicero   b. c 1856
   Graves, Cicero Houston   b. 23 Jul 1881, d. 12 Jun 1934
   Graves, Daniel   b. c 1872
   Graves, Daphne   b. 1904, d. c 1996
   Graves, Jennetta (Nettie)   b. 1872, d. 1946
   Graves, Josephine (Miss Josie)   b. c 1874
   Graves, Mary Ellen   b. c 1890
   Graves, Nadine   b. 26 Oct 1914, d. 13 May 1977
   Graves, Wade Thurman   b. c 1888, d. 1947
   Graves, Wendell   b. 11 Oct 1911, d. 27 Nov 1957
   Graves, William LaFayette   b. 1855, d. 30 Dec 1923
   Oglesby, Alice   b. c 1869
   Oglesby, Ambrose   b. c 1867
   Oglesby, James R.   b. c 1871
   Oglesby, May   b. c 1877
   Rogers, John   b. 9 May 1828, d. 3 May 1907
   Rogers, John Franklin   b. 7 Feb 1866, d. 14 May 1951
   Strickland, Eual D.   b. c 1910, d. Feb 1976
   Ward, J. Clarence
   Ward, Nettie   b. c 1894
   Whitlock, Mary Malinda   b. 29 Nov 1846, d. 20 Feb 1925
Coryell Church
   Duke, Ada   b. 17 Jul 1881, d. 26 Nov 1976
   Graves, Cicero Houston   b. 23 Jul 1881, d. 12 Jun 1934
   Graves, Cora Della   b. 9 Apr 1900, d. 17 Feb 1994
   Graves, Della   b. c 1883
   Graves, Doctor Milton   b. 27 Aug 1894, d. 1963
   Graves, Dossie A.   b. 11 Mar 1905, d. 11 Aug 1941
   Graves, Elizabeth Minerva (Betty)   b. c 1885
   Graves, Eula Ethel   b. 13 Dec 1895, d. 22 Mar 1951
   Graves, Lewis   b. 11 Sep 1826, d. 4 Jun 1894
   Graves, Lewis Frank   b. 11 Sep 1903, d. 1964
   Graves, Mary Ellen   b. c 1890
   Graves, Ora   b. s 1901
   Graves, Orien Arthur   b. 17 Nov 1910, d. 30 Sep 1975
   Graves, Oscar Edward   b. 3 Apr 1898, d. 20 Aug 1938
   Graves, Thomas A.   b. 13 Aug 1873, d. 31 May 1940
   Graves, Wade Thurman   b. c 1888, d. 1947
   Humphries, Emily Stella   b. 7 Apr 1887, d. 8 May 1971
Gatesville
   Graves, Andrew Carroll   b. c 1831, d. 6 Sep 1904
   Graves, Mary Ellen   b. c 1890
   Graves, Thomas A.   b. 13 Aug 1873, d. 31 May 1940
Jonesboro
   Graves, Lewis Bethel   b. 25 Oct 1867, d. 3 Feb 1938
   Graves, Oscar Edward   b. 3 Apr 1898, d. 20 Aug 1938
Killeen
   Graves, Doctor Franklin   b. c 1876, d. 1942
Osage
   Graves, Lewis   b. 11 Sep 1826, d. 4 Jun 1894
   Graves, Opal   b. 8 Mar 1906, d. 11 May 1907
   Whitlock, Abner Brown   b. c 1843, d. 1925
   Whitlock, Isaac D.   b. 1 Dec 1848, d. 8 Feb 1927
   Whitlock, L. P (Witt)   b. 19 Jun 1839, d. 21 Jun 1924
Pidcoke
   Graves, Doctor Franklin   b. c 1876, d. 1942
   Graves, Thomas A.   b. 13 Aug 1873, d. 31 May 1940
Turnerville
   Armstrong, Albert Cullen   b. 10 Jan 1914, d. 16 Feb 1915
   Armstrong, Albert Gather   b. 19 Jan 1893, d. 16 Nov 1956
   Armstrong, Albert Johnston   b. 11 Mar 1868, d. 30 Jun 1954
   Armstrong, Allen E.   b. 15 Mar 1907, d. 6 Jun 1948
   Armstrong, Allie   b. 2 Nov 1902
   Armstrong, Charlie J.   b. 23 Jun 1905, d. 3 Jan 1981
   Armstrong, Donald Earnest   b. 9 Sep 1909, d. 4 Nov 1976
   Armstrong, Jim W.   b. 18 Mar 1895, d. 10 Mar 1910
   Armstrong, Jimmie H.   b. 30 Mar 1912, d. 1 May 1961
   Armstrong, Lee Mahley   b. 8 Oct 1900, d. 21 May 1976
   Armstrong, Margret Louise   b. 6 Jun 1920, d. 1922
   Armstrong, Melvin   b. c 1892
   Armstrong, Stony Raby   b. 18 May 1898, d. 5 Dec 1970
   McKinney, Mary Ethel   b. 7 Mar 1893, d. 22 Feb 1983
   Moore, Nannie   b. 24 Dec 1871, d. 28 May 1912
Dallas County
   Gill, Martha A.   b. c 1825, d. a 11 Jun 1900
   Merritt, Martha Dora   b. 8 Mar 1859, d. 17 Apr 1928
   Ruff, John Will   b. 14 Feb 1882, d. 26 May 1912
   Wilson, William S.   b. c 1824, d. a 11 Jun 1990
Dallas
   Davis, Louisian A.   b. 5 Apr 1849, d. 20 Sep 1915
   Haynes, Crawford Benton   b. 23 Jan 1914, d. 19 Sep 1981
   Nabb, Mary Effie   b. 6 Dec 1889, d. 13 Jul 1970
   Ruff, Walter Leslie   b. 3 Oct 1887, d. 22 Jun 1947
Denton County
   Ruff, Mariah Elizabeth "Lizzie"   b. c 1851, d. 14 Mar 1893
   Terry, Edward Hull   b. 24 Jan 1869, d. 29 Mar 1950
Denton
   Armstrong, Lillian Lee   b. c 1856, d. a 1893
Ector
   Rogers, Olin Duglass   b. 21 Jun 1910, d. 7 Feb 1986
Falls County
Rosebud
   Dagley, Alma Ethel   b. 15 Nov 1882, d. 19 Dec 1936
Fannin County
Bonham
   Terry, Edward Hull   b. 24 Jan 1869, d. 29 Mar 1950
   Terry, Ella   b. Jan 1895
   Terry, Emma   b. Dec 1897
   Terry, Joe E.   b. Jan 1899
Floyd County
Lockney
   Graves, Della   b. c 1883
Foard County
   Lefevre, Francis Regis (Bud)   b. c 1857, d. 28 Dec 1932
Glenrose
   Graves, Paul David   b. 18 Jan 1939, d. 18 Jul 1999
Grimes County
   White, Nancy   b. s 1812
   Wilson, George Z   b. c 1841
   Wilson, Parmelia Amanda   b. 1834
Hamilton
   Lefevre, Frances E.   b. c 1836
Hamilton County
   Armstrong, Stony Raby   b. 18 May 1898, d. 5 Dec 1970
   Graves, Ettie   b. 16 Sep 1899, d. 10 Mar 1984
   Hedgpeth, Joe Gayle   b. 21 Feb 1937, d. 15 Feb 2000
   Hedgpeth, Vernon Esteen   b. c 1907
   Lefevre, Edwin Augustus (Ed)   b. 9 Jan 1879
   Simpson, Lottie   b. c 1880
   Talley, Maggie   b. c 1901
Carlton
   (Graves), Maggie   b. 13 Apr 1871, d. 30 Jan 1918
   (Graves), Wilma A. ?   b. 1906, d. 1998
   Basham, Emmett E.   b. 20 Jul 1895, d. 5 Feb 1964
   Gibson, Audie   b. 28 Aug 1891, d. 16 Dec 1932
   Gibson, Ira J.   b. 1869, d. 1931
   Graves, Cora Della   b. 9 Apr 1900, d. 17 Feb 1994
   Graves, Doctor Milton   b. 27 Aug 1894, d. 1963
   Graves, Dossie A.   b. 11 Mar 1905, d. 11 Aug 1941
   Graves, Frank   b. 26 May 1895, d. 7 Sep 1911
   Graves, Jennetta (Nettie)   b. 1872, d. 1946
   Graves, John Andrew   b. 27 Apr 1863, d. 5 Jan 1933
   Graves, Lewis Bethel   b. 25 Oct 1867, d. 3 Feb 1938
   Graves, Omer V.   b. 1906, d. 1967
   Graves, Oscar Edward   b. 3 Apr 1898, d. 20 Aug 1938
   Lefevre, Clayton   b. 10 Nov 1913, d. c 1980
   Lefevre, Clyde Forest   b. 21 Jun 1904, d. c 1989
   Lefevre, Rhoda Ellen Ophelia   b. 14 Mar 1874, d. 31 Aug 1976
   Short, Rodolph   b. c 1913, d. c 1988
   Whitlock, Mary Malinda   b. 29 Nov 1846, d. 20 Feb 1925
Fairy
   Hedgpeth, Vernon Esteen   b. c 1907
   Hedgpeth, Vernon Ray   b. 15 Feb 1935, d. 31 May 2002
Hamilton
   Hedgpeth, Lewis Madison   b. 17 Feb 1936, d. 17 Jun 1941
Harris County
Houston
   Armstrong, Lee Mahley   b. 8 Oct 1900, d. 21 May 1976
   Reeder, Wlliam G.   b. c 1897
   Ruff, Walter Leslie   b. 3 Oct 1887, d. 22 Jun 1947
Hill
   Rogers, Curtis Edwin   b. 15 Jun 1897, d. Apr 1978
North Part Dist 6
   Rogers, John   b. 9 May 1828, d. 3 May 1907
Hill County
   Cantrell, Ella Florence   b. 4 Dec 1908, d. 17 May 1997
Peoria
   Cantrell, Ella Florence   b. 4 Dec 1908, d. 17 May 1997
   Graves, Lewis Frank   b. 11 Sep 1903, d. 1964
Johnson
Alvarado
   Rogers, John   b. 9 May 1828, d. 3 May 1907
   Rogers, John Milton   b. 25 Oct 1890, d. 14 Dec 1970
Cleburne
   Rogers, Elmer Griffin   b. 7 Nov 1892, d. Jan 1970
   Rogers, Vera Edna   b. 17 Feb 1895, d. 19 Jan 1968
Cleburne,
   Rogers, Ruby Eva   b. 15 Dec 1899, d. 19 Feb 1982
Johnson County
Cleburne
   Elrod, Delia Lee   b. 10 Jan 1890, d. 2 Jun 1949
   Graves, Paul David   b. 18 Jan 1939, d. 18 Jul 1999
   Hargrove, Eula Pearl   b. 8 Aug 1902, d. 24 Jul 1978
   Lefevre, Amanda Elizabeth (Mandie)   b. 17 Dec 1886, d. 21 Mar 1983
   Lefevre, Cleo Oliver   b. 6 Sep 1907, d. 2 Sep 1949
   Lefevre, Clyde Forest   b. 21 Jun 1904, d. c 1989
   Lefevre, John Thomas   b. 3 Oct 1926, d. 30 Jan 1993
   Short, Rodolph   b. c 1913, d. c 1988


Previous Page - Next Page
Main Page - Master Index - Surname Index - Master Place Index - Home Page

Compiler:
Joe Grant
3804 Glenmont Dr., Fort Worth, Texas. 76133

This page was created by John Cardinal's Second Site v1.8.7.
Site updated on 27 April 2006 at 7:08:08 PM from grant; 2,404 people